EP3686290 - Bibliographic data

PROCÉDÉ ET KITS D'IDENTIFICATION D'INHIBITEURS DE CDK9 POUR LE TRAITEMENT DU CANCER

Last update 16/07/2025
Legal status Brevet déchu
Origin Européen

(73) Holder

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

1275 York Avenue
New York, NY 10065
États-Unis d'Amérique

St. Jude Children's Research Hospital

262 Danny Thomas Place
Memphis, TN 38105-3678
États-Unis d'Amérique
(72) Inventors

Scott LOWE

345 E 68th Street Apt. 2 A-C
New York, NY 10065
États-Unis d'Amérique

Charles SHERR

67 Grove Park Circle
Memphis, TN 38117
États-Unis d'Amérique

Chun-Hao HUANG

1233 York Ave. Apt. 18F
New York, NY 10065
États-Unis d'Amérique

Amaia LUJAMBIO

1470 Madison Avenue Hess Building, 6th Floor, No.111
New York, NY 10029
États-Unis d'Amérique
(74) Agent

Mail recipient

Barker Brettell LLP

100 Hagley Road Edgbaston
Birmingham B16 8QQ
Royaume-Uni

(21) Request number EP20157661.8
(22) Request date 02/04/2015

(11) Publication number EP3686290
Publication date 23/08/2023

(54) Title of the invention PROCÉDÉ ET KITS D'IDENTIFICATION D'INHIBITEURS DE CDK9 POUR LE TRAITEMENT DU CANCER
(51) International classification C12Q   1/6886C12Q   1/68G01N 33/574A61K 48/00A61K 31/70A61K 31/445A61K 45/06A61K 31/40A61K 31/404A61K 31/44A61K 31/4545A61K 31/4745
International classification (before reform) None

Claimed priority

(31) Number: 201461975401 P
(32) Date: 04/04/2014
(33) Country: US

Initial application None
Divisional application None

Expected annuity Annuity: 10 - Amount: 195 € - Due date 30/04/2024
Surtax: 10 - Amount: 39 € - Due date 04/11/2024
Last annuity None

Publication None
History

Publication de la délivrance du brevet européen - Legal date 23/08/2023


Modification du mandataire OEB du brevet européen - Legal date 25/08/2023


Entrée en période de grâce du brevet d'invention - Legal date 01/05/2024


Déchéance du brevet d'invention après période de grâce - Legal date 30/04/2024